-
DBS CLOTHING LIMITED - Unit 8a Plaxton Park Cayton Low Road, Eastfield, Scarborough, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08359183
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 8a Plaxton Park Cayton Low Road
- Eastfield
- Scarborough
- North Yorkshire
- YO11 3BQ Unit 8a Plaxton Park Cayton Low Road, Eastfield, Scarborough, North Yorkshire, YO11 3BQ UK
Management
- Geschäftsführung
- AZIZ, Wayne Mohammed
- CHAMBERS, Christopher James
- GILL, Barry John
- THOMPSON, David
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.01.2013
- Alter der Firma 2013-01-14 11 Jahre
- SIC/NACE
- 46420
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Samuel Harry Joseph Kay
- Mr Barry John Gill
- Mr David Thompson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- administration
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-05-31
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-27
- Letzte Einreichung: 2023-01-13
-
DBS CLOTHING LIMITED Firmenbeschreibung
- DBS CLOTHING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08359183. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.01.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46420" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 8A Plaxton Park Cayton Low Road erreicht werden.
Jetzt sichern DBS CLOTHING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dbs Clothing Limited - Unit 8a Plaxton Park Cayton Low Road, Eastfield, Scarborough, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2013-01-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DBS CLOTHING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-01-27) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-02-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-26) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-08-02) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-08-04) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-26) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-01) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-05-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-05-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-03-02) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-04) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-04) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-23) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-05-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-30) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-02) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-05-02) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-24) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-25) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-25) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-20) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-26) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-09-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-06-11) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-12-13) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-05-09) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-03-19) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-01-15) - AP01
-
incorporation-company (2013-01-14) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2013-09-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-10) - AP01