-
DESTINY AUTOMATE LTD - Aw House, 6-8 Stuart Street, Luton, Bedfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08414530
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Aw House
- 6-8 Stuart Street
- Luton
- Bedfordshire
- LU1 2SJ
- England Aw House, 6-8 Stuart Street, Luton, Bedfordshire, LU1 2SJ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ARTHUR, Jeannie Helen
- SORQVIST, Lars Patrik
- VAN RYMENANT, Joris
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.02.2013
- Alter der Firma 2013-02-21 11 Jahre
- SIC/NACE
- 61900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Qunifi Holdings Limited
- -
- -
- -
- Destiny Uk Midco Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- QUNIFI LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-02-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-01
- Letzte Einreichung: 2022-08-18
-
DESTINY AUTOMATE LTD Firmenbeschreibung
- DESTINY AUTOMATE LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08414530. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.02.2013 registriert. DESTINY AUTOMATE LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen QUNIFI LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "61900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 28.02.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Aw House erreicht werden.
Jetzt sichern DESTINY AUTOMATE LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Destiny Automate Ltd - Aw House, 6-8 Stuart Street, Luton, Bedfordshire, Grossbritannien
- 2013-02-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DESTINY AUTOMATE LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-23) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-08-22) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-08-04) - PSC05
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-07-08) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-06-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-05-30) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-01-14) - MR04
-
certificate-change-of-name-company (2022-04-28) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-03-24) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-03-24) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-03-24) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2022-03-30) - AA01
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-07) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-27) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-08) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-09-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-22) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-24) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-22) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-22) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-23) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-10-25) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-23) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-10-26) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-19) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-04) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-10-27) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-11-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-19) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-02-17) - CERTNM
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-02-16) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-02-16) - AP04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-11-14) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-31) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-02-21) - NEWINC