-
100 CLERKENWELL ROAD LIMITED - C/O James Cowper Kreston The White Building, 1-4 Cumberland Place, Southampton, SO15 2NP, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08504351
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O James Cowper Kreston The White Building
- 1-4 Cumberland Place
- Southampton
- SO15 2NP C/O James Cowper Kreston The White Building, 1-4 Cumberland Place, Southampton, SO15 2NP UK
Management
- Geschäftsführung
- BUTT, Abidah Begum
- BUTT, Simea
- HUSSAIN, Sheazad
- HUSSAIN, Zain Al-Abadean
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.04.2013
- Gelöscht am:
- 2023-03-17
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Zain Al-Abadean Hussain
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-08-14
- Letzte Einreichung: 2020-07-31
-
100 CLERKENWELL ROAD LIMITED Firmenbeschreibung
- 100 CLERKENWELL ROAD LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08504351. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 25.04.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o James Cowper Kreston The White Building erreicht werden.
Jetzt sichern 100 CLERKENWELL ROAD LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 100 Clerkenwell Road Limited - C/O James Cowper Kreston The White Building, 1-4 Cumberland Place, Southampton, SO15 2NP, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 100 CLERKENWELL ROAD LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-03-17) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-in-administration-progress-report (2022-01-17) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2022-06-08) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2022-07-22) - AM10
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2022-12-17) - AM23
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-07-27) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2021-11-08) - AM19
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-05) - AD01
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2021-01-14) - AM02
-
liquidation-in-administration-proposals (2021-02-17) - AM03
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2021-03-09) - AM06
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-30) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-04-08) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-04) - CS01
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2020-12-23) - AM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-13) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-17) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-05) - PSC01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-07-08) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-30) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-27) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-18) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-29) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-14) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-12-23) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-09) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-23) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-04-02) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-08) - AR01
-
resolution (2015-04-02) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-05-02) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-11-20) - MR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-07-14) - SH08
-
resolution (2014-06-25) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-18) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-05-16) - TM01
-
incorporation-company (2013-04-25) - NEWINC