-
A & B FENCING (CIREN) LTD - 9 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08512501
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 9 Commerce Road
- Lynchwood
- Peterborough
- Cambridgeshire
- PE2 6LR
- United Kingdom 9 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, PE2 6LR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- KENNEALLY, Christopher Martin
- KENNEALLY, Ivalo Møller
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 01.05.2013
- Alter der Firma 2013-05-01 11 Jahre
- SIC/NACE
- 43390
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Greenlands Fencing Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- BLUEBELL PROPERTY MAINTENANCE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-31
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-05-15
- Letzte Einreichung: 2024-05-01
-
A & B FENCING (CIREN) LTD Firmenbeschreibung
- A & B FENCING (CIREN) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08512501. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 01.05.2013 registriert. A & B FENCING (CIREN) LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen BLUEBELL PROPERTY MAINTENANCE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43390" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 9 Commerce Road erreicht werden.
Jetzt sichern A & B FENCING (CIREN) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: A & B Fencing (Ciren) Ltd - 9 Commerce Road, Lynchwood, Peterborough, Cambridgeshire, Grossbritannien
- 2013-05-01
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu A & B FENCING (CIREN) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-updates (2024-05-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-05-23) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-04) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-04-05) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-04-05) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-03-17) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-07) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-07) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2023-07-19) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-03-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-03-07) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-18) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-02) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-02-12) - PSC01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-12) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-02-12) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-11-25) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-02) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-07) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-17) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-04-21) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-01-21) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-10-02) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-02) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-01) - CERTNM
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-05-01) - NEWINC