-
COMPLY LOGISTICS LIMITED - Units 3 & 4 Kiln Way Industrial Estate, Swadlincote, DE11 8ED, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08588735
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Units 3 & 4 Kiln Way Industrial Estate
- Swadlincote
- DE11 8ED
- United Kingdom Units 3 & 4 Kiln Way Industrial Estate, Swadlincote, DE11 8ED, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- DYTHAM, Stuart George
- DYTHAM, Ann Marie
- Prokuristen
- DYTHAM, Ann Marie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-28 11 Jahre
- SIC/NACE
- 64204
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Stuart George Dytham
- Mrs Ann Marie Dytham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-23
- Letzte Einreichung: 2023-06-09
-
COMPLY LOGISTICS LIMITED Firmenbeschreibung
- COMPLY LOGISTICS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08588735. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64204" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Units 3 & 4 Kiln Way Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern COMPLY LOGISTICS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Comply Logistics Limited - Units 3 & 4 Kiln Way Industrial Estate, Swadlincote, DE11 8ED, United Kingdom, Grossbritannien
- 2013-06-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COMPLY LOGISTICS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2024-04-29) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2024-06-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2024-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-29) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2023-09-06) - AA01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-06-15) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-05) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-05-31) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-05-31) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2022-06-09) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-09-28) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-09-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-12) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-11) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-06) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-06) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-06) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-04-26) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-01) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-29) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-22) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-05-22) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-03-19) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-28) - NEWINC