-
DLP NORTH WEST LIMITED - C/O Sue Barker Accountancy Services Ltd Cunliffe House, Longsight Road, Langho, Blackburn, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08700621
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Sue Barker Accountancy Services Ltd Cunliffe House
- Longsight Road, Langho
- Blackburn
- Lancashire
- BB6 8AD
- England C/O Sue Barker Accountancy Services Ltd Cunliffe House, Longsight Road, Langho, Blackburn, Lancashire, BB6 8AD, England UK
Management
- Geschäftsführung
- EATOUGH, Neil Redman
- MULLIN, Calista
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.09.2013
- Gelöscht am:
- 2023-01-31
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Dexter Paints Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- DAVID LLOYD PARTNERSHIP LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-06-30
- Letzte Einreichung: 2019-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-18
- Letzte Einreichung: 2020-10-04
-
DLP NORTH WEST LIMITED Firmenbeschreibung
- DLP NORTH WEST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08700621. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 20.09.2013 registriert. DLP NORTH WEST LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DAVID LLOYD PARTNERSHIP LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Sue Barker Accountancy Services Ltd Cunliffe House erreicht werden.
Jetzt sichern DLP NORTH WEST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dlp North West Limited - C/O Sue Barker Accountancy Services Ltd Cunliffe House, Longsight Road, Langho, Blackburn, Lancashire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DLP NORTH WEST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-28) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-29) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-03-21) - SH03
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-07) - PSC07
-
resolution (2019-02-04) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-25) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-21) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-04-17) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-10-04) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-04) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-11-21) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-10-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-30) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-21) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-09-18) - PSC05
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-09-18) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-23) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-15) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-14) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-11-11) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-11) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-11) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-12) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-11-10) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-28) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-30) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-08-19) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-19) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-17) - AP01
-
incorporation-company (2013-09-20) - NEWINC