-
SNAFFLING PIG LIMITED - Unit 5 Farmbrough Close, Aylesbury, Buckinghamshire, HP20 1DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08811267
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 5 Farmbrough Close
- Aylesbury
- Buckinghamshire
- HP20 1DQ Unit 5 Farmbrough Close, Aylesbury, Buckinghamshire, HP20 1DQ UK
Management
- Geschäftsführung
- COLEMAN, Nicholas Charles
- SILVA, Udhi
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-11 10 Jahre
- SIC/NACE
- 10890
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Nicholas Charles Coleman
- Mr Udhi Silva
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- GIGGLING PIG LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800JXEZBFYKRADU98
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-07
- Letzte Einreichung: 2023-01-24
-
SNAFFLING PIG LIMITED Firmenbeschreibung
- SNAFFLING PIG LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08811267. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2013 registriert. SNAFFLING PIG LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen GIGGLING PIG LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "10890" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 5 Farmbrough Close erreicht werden.
Jetzt sichern SNAFFLING PIG LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Snaffling Pig Limited - Unit 5 Farmbrough Close, Aylesbury, Buckinghamshire, HP20 1DQ, Grossbritannien
- 2013-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SNAFFLING PIG LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-person-director-company-with-change-date (2024-02-08) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2024-02-08) - PSC04
keyboard_arrow_right 2023
-
resolution (2023-08-07) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2023-08-07) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-03-07) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-02-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
resolution (2021-01-28) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2021-01-29) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-04-21) - SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-03-28) - PSC08
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-27) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-28) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-12-10) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-28) - PSC01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-03-28) - PSC09
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-02) - TM01
-
resolution (2019-07-09) - RESOLUTIONS
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2019-01-24) - RP04AR01
-
capital-return-purchase-own-shares (2019-08-08) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-14) - CS01
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2019-09-06) - RP04TM01
-
resolution (2019-09-17) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-19) - AA
-
capital-alter-shares-subdivision (2019-12-10) - SH02
-
capital-cancellation-shares (2019-07-09) - SH06
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-07) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-23) - MR01
-
legacy (2018-11-20) - RP04CS01
-
capital-allotment-shares (2018-11-26) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-12-07) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-12-07) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
legacy (2017-01-10) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-12-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-27) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-15) - AA
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2016-08-16) - RP04AR01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-08-03) - SH02
-
capital-allotment-shares (2016-08-03) - SH01
-
resolution (2016-08-02) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-06) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-01) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-08) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2015-06-24) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-06-03) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-11) - NEWINC