-
SOUTH STREET PROPERTIES LIMITED - Spitalfields House, Stirling Way, Borehamwood, Herts, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08979310
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Spitalfields House
- Stirling Way
- Borehamwood
- Herts
- WD6 2FX
- England Spitalfields House, Stirling Way, Borehamwood, Herts, WD6 2FX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GRANDITER, Marc Alexander
- GRANDITER, Monique
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-04 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Marc Alexander Granditer
- -
- Mrs Monique Granditer
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-31
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-08-12
- Letzte Einreichung: 2023-07-29
-
SOUTH STREET PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- SOUTH STREET PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08979310. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.04.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.04.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Spitalfields House erreicht werden.
Jetzt sichern SOUTH STREET PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: South Street Properties Limited - Spitalfields House, Stirling Way, Borehamwood, Herts, Grossbritannien
- 2014-04-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SOUTH STREET PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-17) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-02-17) - AAMD
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-08-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-12-21) - DISS40
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-12-20) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-20) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-12-12) - AD01
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-12-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2022-11-22) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-09-22) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-07-28) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-04-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-28) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-07-20) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-20) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-29) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-28) - PSC01
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2021-09-24) - MR05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-10-20) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-28) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-07-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-21) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-01) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-01) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-04-04) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-07) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-16) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-04-07) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-04) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-04-23) - CH01