-
OWEN ATV'S & GARDEN MACHINERY CENTRE LIMITED - The Old Vicarage, 51 St John Street, Ashbourne, Derbyshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09035280
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Old Vicarage
- 51 St John Street
- Ashbourne
- Derbyshire
- DE6 1GP The Old Vicarage, 51 St John Street, Ashbourne, Derbyshire, DE6 1GP UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMAS, Paul Leslie
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 33120
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Llyn Atvs Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-26
- Letzte Einreichung: 2023-05-12
-
OWEN ATV'S & GARDEN MACHINERY CENTRE LIMITED Firmenbeschreibung
- OWEN ATV'S & GARDEN MACHINERY CENTRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09035280. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "33120" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über The Old Vicarage erreicht werden.
Jetzt sichern OWEN ATV'S & GARDEN MACHINERY CENTRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Owen Atv's & Garden Machinery Centre Limited - The Old Vicarage, 51 St John Street, Ashbourne, Derbyshire, Grossbritannien
- 2014-05-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu OWEN ATV'S & GARDEN MACHINERY CENTRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-26) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-01-08) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-07) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-07) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-26) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-01) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-12-01) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-12-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-28) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-06-01) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-06-01) - PSC04
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-06-01) - TM02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-04-11) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-22) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-02-05) - MR04
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2019-02-05) - MR05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-11) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-11) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-06) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-07-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-18) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-22) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-03) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-03-24) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-03) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-05-15) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-10-16) - CH03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-31) - MR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-06-26) - CH03
-
incorporation-company (2014-05-12) - NEWINC
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-26) - CH01