-
CHANNEL FACILITIES MANAGEMENT LIMITED - 4a Canada Road, Walmer, Deal, CT14 7DZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09164202
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4a Canada Road
- Walmer
- Deal
- CT14 7DZ
- England 4a Canada Road, Walmer, Deal, CT14 7DZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GREGORY-FOSTER, Joseph Peter
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.08.2014
- Alter der Firma 2014-08-06 10 Jahre
- SIC/NACE
- 96090
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Darren Gregory-Foster
- Mr Joseph Gregory-Foster
- Mr Darren Gregory-Foster
- Mr Joseph Gregory-Foster
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Voluntary Arrangement
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-05-30
- Letzte Einreichung: 2022-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-28
- Letzte Einreichung: 2023-03-14
-
CHANNEL FACILITIES MANAGEMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- CHANNEL FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09164202. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.08.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96090" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 4A Canada Road erreicht werden.
Jetzt sichern CHANNEL FACILITIES MANAGEMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Channel Facilities Management Limited - 4a Canada Road, Walmer, Deal, CT14 7DZ, Grossbritannien
- 2014-08-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHANNEL FACILITIES MANAGEMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-03-13) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-03-16) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-03-15) - PSC04
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2023-05-09) - CVA3
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-05-02) - AD01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-25) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-26) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2022-05-17) - CVA3
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-21) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2021-05-19) - CVA3
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-29) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2020-03-25) - CVA1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-18) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-26) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-30) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-04-24) - CH01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-05-31) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-07) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-10-17) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-06) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-10) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-09-29) - AD01
-
capital-allotment-shares (2016-09-09) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-21) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-06) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-10) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-08-06) - NEWINC