-
COURT HOUSE CARE HOLDINGS LIMITED - Price Davis, The Old Baptist Chapel New Street, Painswick, Stroud, GL6 6XH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09216383
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Price Davis, The Old Baptist Chapel New Street
- Painswick
- Stroud
- GL6 6XH
- England Price Davis, The Old Baptist Chapel New Street, Painswick, Stroud, GL6 6XH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ADAMS, Michael William
- LLOYD, Linda Kathleen
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.09.2014
- Alter der Firma 2014-09-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Linda Kathleen Lloyd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CHARCO 80 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-01-28
- Letzte Einreichung: 2023-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-02-02
- Letzte Einreichung: 2023-01-19
-
COURT HOUSE CARE HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- COURT HOUSE CARE HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09216383. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.09.2014 registriert. COURT HOUSE CARE HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CHARCO 80 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Price Davis, The Old Baptist Chapel New Street erreicht werden.
Jetzt sichern COURT HOUSE CARE HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Court House Care Holdings Limited - Price Davis, The Old Baptist Chapel New Street, Painswick, Stroud, GL6 6XH, Grossbritannien
- 2014-09-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu COURT HOUSE CARE HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-01-27) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-01-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-02-06) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-02-06) - PSC04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-06) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-10) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-01-28) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-27) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-04-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-27) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-01-31) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-04-25) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-01-09) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-24) - AP01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-01-28) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-07-04) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-01-30) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-09-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-07) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2017-07-04) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-09-09) - DISS40
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-03-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-04-05) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-18) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-04-09) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-12) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-13) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-02-13) - TM01
-
change-of-name-notice (2015-02-18) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-02-18) - CERTNM
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-27) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-04) - AP01
-
resolution (2015-03-12) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2015-03-12) - MA
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-03-12) - SH08
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2015-03-12) - SH10
-
capital-allotment-shares (2015-03-12) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-03-16) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-02-12) - TM02
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-09-12) - NEWINC