-
-
DUDLEY HOUSE (COVENT GARDEN) LTD - Third Floor One London Square, Cross Lanes, Guildford, GU1 1UN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09496586
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Third Floor One London Square
- Cross Lanes
- Guildford
- GU1 1UN Third Floor One London Square, Cross Lanes, Guildford, GU1 1UN UK
Management
- Geschäftsführung
- CHRISTIAN, Phillip Cecil
- SHAW, Stephen James
- Prokuristen
- WHITE HOUSE SECRETARIES LTD
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.03.2015
- Alter der Firma 2015-03-18 9 Jahre
- SIC/NACE
- 41202
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Phillip Cecil Christian
- Mr Stephen James Shaw
- Sarisbury Investments Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-02-28
- Letzte Einreichung: 2017-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-04-09
- Letzte Einreichung: 2018-03-26
-
DUDLEY HOUSE (COVENT GARDEN) LTD Firmenbeschreibung
- DUDLEY HOUSE (COVENT GARDEN) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09496586. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.03.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41202" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Third Floor One London Square erreicht werden.
Jetzt sichern DUDLEY HOUSE (COVENT GARDEN) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dudley House (Covent Garden) Ltd - Third Floor One London Square, Cross Lanes, Guildford, GU1 1UN, Grossbritannien
- 2015-03-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DUDLEY HOUSE (COVENT GARDEN) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-08-30) - LIQ03
-
liquidation-in-administration-move-to-creditors-voluntary-liquidation (2021-04-30) - AM22
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-05-14) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-10-15) - AD01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-05-30) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2020-05-22) - AM19
-
liquidation-in-administration-progress-report (2020-11-30) - AM10
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-11-27) - AM10
-
liquidation-in-administration-progress-report (2019-06-12) - AM10
-
liquidation-in-administration-extension-of-period (2019-04-18) - AM19
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-03) - CS01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2018-12-08) - AM10
-
liquidation-administration-notice-deemed-approval-of-proposals (2018-07-18) - AM06
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2018-07-03) - AM02
-
liquidation-in-administration-proposals (2018-06-29) - AM03
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2018-05-31) - AM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-08) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-08) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-06) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-10-27) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-01-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-20) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-03-20) - SH01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2015-03-26) - AP04
-
capital-allotment-shares (2015-03-26) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-10-08) - SH08
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-04) - AP01
-
resolution (2015-10-08) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-26) - AR01
-
incorporation-company (2015-03-18) - NEWINC