-
VILLAGE COMMUNICATIONS LTD - Ground Floor, 37 Central Street, London, EC1V 8AB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09952467
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ground Floor
- 37 Central Street
- London
- EC1V 8AB
- United Kingdom Ground Floor, 37 Central Street, London, EC1V 8AB, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- COX, Richard
- MACNAIR, Deidre
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.01.2016
- Alter der Firma 2016-01-14 8 Jahre
- SIC/NACE
- 73110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- THE VILLAGE 2016 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2018-01-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-15
- Letzte Einreichung: 2022-11-01
-
VILLAGE COMMUNICATIONS LTD Firmenbeschreibung
- VILLAGE COMMUNICATIONS LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09952467. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.01.2016 registriert. VILLAGE COMMUNICATIONS LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen THE VILLAGE 2016 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "73110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.01.2018.Die Firma kann schriftlich über Ground Floor erreicht werden.
Jetzt sichern VILLAGE COMMUNICATIONS LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Village Communications Ltd - Ground Floor, 37 Central Street, London, EC1V 8AB, Grossbritannien
- 2016-01-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VILLAGE COMMUNICATIONS LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-09-14) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-01) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-09-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-06) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-06) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-13) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-25) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-22) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-30) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-04-30) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-26) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-26) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-02-26) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-24) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-22) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-08-01) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-03) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-03-13) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-01) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2016-08-19) - CERTNM
-
incorporation-company (2016-01-14) - NEWINC