-
D W PLASTICS GROUP LTD - 36 Fifth Avenue, Havant, Hampshire, PO9 2PL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10241438
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 36 Fifth Avenue
- Havant
- Hampshire
- PO9 2PL
- England 36 Fifth Avenue, Havant, Hampshire, PO9 2PL, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BURLEY, Sue Elizabeth
- DAVIES, Andrew
- JONES, Simon Andrew
- WHITE, Paul Matthew
- Prokuristen
- BURLEY, Sue Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.06.2016
- Alter der Firma 2016-06-20 8 Jahre
- SIC/NACE
- 22210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Panoramic Growth Fund 2 Lp, Acting By Its General Partner Panoramic Growth Equity (Gp2) Llp
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- HAMSARD 3416 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2023-06-16
-
D W PLASTICS GROUP LTD Firmenbeschreibung
- D W PLASTICS GROUP LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10241438. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.06.2016 registriert. D W PLASTICS GROUP LTD hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HAMSARD 3416 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22210" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 36 Fifth Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern D W PLASTICS GROUP LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: D W Plastics Group Ltd - 36 Fifth Avenue, Havant, Hampshire, PO9 2PL, Grossbritannien
- 2016-06-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu D W PLASTICS GROUP LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-05-18) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-28) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-08-30) - MR04
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2021-11-01) - MR05
-
mortgage-charge-whole-release-with-charge-number (2021-11-01) - MR05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-09-08) - MR01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-10-02) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-10-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-19) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-13) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-23) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-04-03) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-28) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-08) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-allotment-shares (2017-01-05) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-01) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-30) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-06-20) - NEWINC
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-07) - AD01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-12-29) - SH02
-
resolution (2016-12-06) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-12-06) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-02) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-07) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-10-07) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-10-07) - TM02
-
resolution (2016-12-29) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-10-07) - AP03