-
GENERAL CATERING SERVICES LIMITED - Hunter House 109 Snakes Lane West, Woodford Green, Essex, IG8 0DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10371198
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hunter House 109 Snakes Lane West
- Woodford Green
- Essex
- IG8 0DY Hunter House 109 Snakes Lane West, Woodford Green, Essex, IG8 0DY UK
Management
- Geschäftsführung
- MOSTAFA, Taher Ahmed Taher
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.09.2016
- Gelöscht am:
- 2024-07-11
- SIC/NACE
- 56102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Taher Ahmed Taher Mostafa
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-09-17
- Letzte Einreichung: 2022-09-03
-
GENERAL CATERING SERVICES LIMITED Firmenbeschreibung
- GENERAL CATERING SERVICES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10371198. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 12.09.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56102" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2020 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Hunter House 109 Snakes Lane West erreicht werden.
Jetzt sichern GENERAL CATERING SERVICES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: General Catering Services Limited - Hunter House 109 Snakes Lane West, Woodford Green, Essex, IG8 0DY, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GENERAL CATERING SERVICES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-07-11) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2024-04-11) - LIQ14
-
mortgage-satisfy-charge-full (2024-01-29) - MR04
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2024-01-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-12-20) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2022-12-20) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2022-12-20) - LIQ02
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2022-12-09) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2022-11-29) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-29) - CS01
-
resolution (2022-12-20) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-07) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-08-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-09-03) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-08-04) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-09-03) - PSC01
-
gazette-notice-compulsory (2021-09-07) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-09-08) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-10-28) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2020-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-11) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-11) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-06-28) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-12) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-12) - PSC07
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-10) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-10) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-07-03) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-07-03) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-03) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-06-06) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-05-30) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-05-10) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-06) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-12) - PSC01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-12) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-03) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
incorporation-company (2016-09-12) - NEWINC