-
CONSENSUS 2013 PROPERTIES LIMITED - 3 The Courtyards Phoenix Square, Wyncolls Road, Colchester, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10389454
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3 The Courtyards Phoenix Square
- Wyncolls Road
- Colchester
- Essex
- CO4 9PE
- England 3 The Courtyards Phoenix Square, Wyncolls Road, Colchester, Essex, CO4 9PE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- KEYS, Paula Bridget Sarah
- HOLMAN, Benjamin Trevor
- Prokuristen
- HOLMAN, Benjamin Trevor
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 22.09.2016
- Alter der Firma 2016-09-22 7 Jahre
- SIC/NACE
- 87900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Sscp Pegasus Bidco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-05
- Letzte Einreichung: 2023-09-21
-
CONSENSUS 2013 PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- CONSENSUS 2013 PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10389454. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 22.09.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "87900" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3 The Courtyards Phoenix Square erreicht werden.
Jetzt sichern CONSENSUS 2013 PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Consensus 2013 Properties Limited - 3 The Courtyards Phoenix Square, Wyncolls Road, Colchester, Essex, Grossbritannien
- 2016-09-22
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CONSENSUS 2013 PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-12-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-12-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-25) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2023-06-05) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2023-06-05) - AP03
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-10-18) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2022-10-04) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-10-04) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-10-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-04-05) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-04-04) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-02-08) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-02-08) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-08-02) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-11-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-04-23) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-02-24) - PSC05
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2020-12-15) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-12-24) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-15) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-15) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-09-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-21) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-09-21) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-10-11) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-10) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-18) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2016-11-10) - AA01
-
incorporation-company (2016-09-22) - NEWINC