-
HAMMER FILM HOLDINGS TWO LIMITED - 16 Soho Square, London, United Kingdom, W1D 3QH, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10406938
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 16 Soho Square
- London
- United Kingdom
- W1D 3QH 16 Soho Square, London, United Kingdom, W1D 3QH UK
Management
- Geschäftsführung
- LACK, Jonathan Anthony James
- GORE, John Ellis
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.10.2016
- Alter der Firma 2016-10-03 7 Jahre
- SIC/NACE
- 59111
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Hammer Films And Productions Holdings Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-16
- Letzte Einreichung: 2022-10-02
-
HAMMER FILM HOLDINGS TWO LIMITED Firmenbeschreibung
- HAMMER FILM HOLDINGS TWO LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10406938. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.10.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "59111" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 16 Soho Square erreicht werden.
Jetzt sichern HAMMER FILM HOLDINGS TWO LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hammer Film Holdings Two Limited - 16 Soho Square, London, United Kingdom, W1D 3QH, Grossbritannien
- 2016-10-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HAMMER FILM HOLDINGS TWO LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-08-31) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-08-30) - TM01
-
memorandum-articles (2023-08-29) - MA
-
resolution (2023-08-29) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-08-20) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-08-14) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-06-09) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-02-09) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-01-09) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2023-08-30) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-08-30) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-08-31) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-08-31) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2023-09-07) - MR04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-12-08) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-12-08) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-12-08) - PSC02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-12-08) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-12-08) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-06) - CS01
-
resolution (2019-10-31) - RESOLUTIONS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-15) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-10-10) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-16) - AA
-
legacy (2019-03-11) - RP04CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-03-01) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-01) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-02-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-05-11) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-26) - AP01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-09) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-09) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-06) - CS01
-
resolution (2018-04-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-10-09) - PSC04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-09) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2017-12-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-11-02) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2016-10-03) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-21) - MR01