-
NAPLES STREET PROPERTIES LIMITED - Unit 3 Birchwood One Business Park Dewhurst Road, Birchwood, Warrington, WA3 7GB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 10788197
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 3 Birchwood One Business Park Dewhurst Road
- Birchwood
- Warrington
- WA3 7GB
- England Unit 3 Birchwood One Business Park Dewhurst Road, Birchwood, Warrington, WA3 7GB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- ISMAIL, Simon Anthony
- SADDIQUE, Javed Akthar
- Prokuristen
- ISMAIL, Joanne Elizabeth
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.05.2017
- Alter der Firma 2017-05-24 7 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Homezzz Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-30
- Letzte Einreichung: 2023-05-16
-
NAPLES STREET PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- NAPLES STREET PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 10788197. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.05.2017 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 3 Birchwood One Business Park Dewhurst Road erreicht werden.
Jetzt sichern NAPLES STREET PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Naples Street Properties Limited - Unit 3 Birchwood One Business Park Dewhurst Road, Birchwood, Warrington, WA3 7GB, Grossbritannien
- 2017-05-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NAPLES STREET PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2023-01-06) - CH03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-05-25) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-07-25) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-11-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-29) - CS01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2020-06-26) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-21) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-05-07) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-05) - CS01
-
memorandum-articles (2018-12-28) - MA
-
resolution (2018-12-28) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-19) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-12-18) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-08) - MR01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-06) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-06) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-11-05) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-11-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-02) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-11-02) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-10-30) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-08-08) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-05) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-09-28) - MR01
-
incorporation-company (2017-05-24) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2017-09-04) - AA01