-
PARKER RESIDENTIAL LIMITED - The Diamond Centre, Market Street, Magherafelt, BT45 6ED, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI601654
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Diamond Centre
- Market Street
- Magherafelt
- BT45 6ED The Diamond Centre, Market Street, Magherafelt, BT45 6ED UK
Management
- Geschäftsführung
- FEARON, Gerard James
- FEARON, Richard
- MARGEY, Conor Peter
- O'KANE, Niall Francis
- Prokuristen
- DEVLIN, Siobhan Margaret
- DOHERTY, Deborah Ann
- FEARON, Maeve
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 17.12.2009
- Alter der Firma 2009-12-17 14 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-30
- Letzte Einreichung: 2020-09-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-17
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-12-17
-
PARKER RESIDENTIAL LIMITED Firmenbeschreibung
- PARKER RESIDENTIAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI601654. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 17.12.2009 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 3 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31/12/2010 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 17.12.2012.Die Firma kann schriftlich über The Diamond Centre erreicht werden.
Jetzt sichern PARKER RESIDENTIAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Parker Residential Limited - The Diamond Centre, Market Street, Magherafelt, BT45 6ED, Grossbritannien
- 2009-12-17
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PARKER RESIDENTIAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-14) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-12) - AD01
-
liquidation-declaration-of-solvency-northern-ireland (2021-01-12) - 4.71(NI)
-
liquidation-appointment-of-liquidator (2021-01-12) - VL1
-
resolution (2021-01-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2020-11-27) - AA01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-07-20) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-14) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-21) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-02-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-07-05) - AP03
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-18) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-18) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-27) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-01-07) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-02-28) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-12-17) - AA
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-12-18) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2012-05-28) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-01-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-10-26) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-09-19) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-01-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2010
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-10-04) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2010-09-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2010-08-24) - SH01
keyboard_arrow_right 2009
-
incorporation-company (2009-12-17) - NEWINC