-
MEDSTAR LOCUMS LIMITED - 55-59 Adelaide Street, Belfast, Antrim, BT2 8FE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI605520
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 55-59 Adelaide Street
- Belfast
- Antrim
- BT2 8FE 55-59 Adelaide Street, Belfast, Antrim, BT2 8FE UK
Management
- Geschäftsführung
- SINGH, Pankaj Kumar, Dr
- TOMAR, Juhi
- Prokuristen
- TOMAR, Juhi
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.12.2010
- Gelöscht am:
- 2021-09-28
- SIC/NACE
- 86101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Dr Pankaj Kumar Singh
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2019-03-31
- Letzte Einreichung: 2017-06-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-12-14
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-09-17
- Letzte Einreichung: 2018-09-03
-
MEDSTAR LOCUMS LIMITED Firmenbeschreibung
- MEDSTAR LOCUMS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI605520. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 14.12.2010 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86101" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2012 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 14.12.2012.Die Firma kann schriftlich über 55-59 Adelaide Street erreicht werden.
Jetzt sichern MEDSTAR LOCUMS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Medstar Locums Limited - 55-59 Adelaide Street, Belfast, Antrim, BT2 8FE, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MEDSTAR LOCUMS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
gazette-dissolved-compulsory (2021-09-28) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2019
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2019-07-06) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-02-17) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-02-16) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-17) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-05-28) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2018-07-07) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsory (2018-05-29) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-23) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-16) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-29) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-22) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-09) - CS01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-03-24) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-24) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-03-01) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-08-13) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-23) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-05) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-24) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-24) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-17) - MR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-01-26) - SH08
-
gazette-notice-compulsory (2015-01-02) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-26) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-01-24) - DISS40
-
capital-allotment-shares (2015-01-21) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-01-21) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-01-21) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-04-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-03-27) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2014-03-04) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2014-02-22) - DISS16(SOAS)
-
gazette-notice-compulsary (2014-01-03) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-01-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-02-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2012-02-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-09-14) - AA
keyboard_arrow_right 2011
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2011-06-13) - AD01
keyboard_arrow_right 2010
-
incorporation-company (2010-12-14) - NEWINC