-
XPERIENCE DYNAMICS LIMITED - 11 Ferguson Drive, Knockmore Hill Industrial Park, Lisburn, County Antrim, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- NI623202
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 Ferguson Drive
- Knockmore Hill Industrial Park
- Lisburn
- County Antrim
- BT28 2EX 11 Ferguson Drive, Knockmore Hill Industrial Park, Lisburn, County Antrim, BT28 2EX UK
Management
- Geschäftsführung
- CAVEY, Andrew
- KINKEAD, Mark
- MCLEISH, Michael John
- O'KANE, Francis Iain
- O'NEILL, Gerard
- Prokuristen
- LYNCH, Paula
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-04 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62020
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Xperience Group Holdings Ltd
- Xperience Group Holdings Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-09-30
- Letzte Einreichung: 2021-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-18
- Letzte Einreichung: 2023-03-04
-
XPERIENCE DYNAMICS LIMITED Firmenbeschreibung
- XPERIENCE DYNAMICS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. NI623202. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62020" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 11 Ferguson Drive erreicht werden.
Jetzt sichern XPERIENCE DYNAMICS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Xperience Dynamics Limited - 11 Ferguson Drive, Knockmore Hill Industrial Park, Lisburn, County Antrim, Grossbritannien
- 2014-03-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu XPERIENCE DYNAMICS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-03-13) - CS01
-
resolution (2023-04-25) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2023-02-22) - MR01
-
memorandum-articles (2023-01-16) - MA
-
resolution (2023-01-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2022
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-02-28) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-15) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-09-28) - AA
-
resolution (2022-10-27) - RESOLUTIONS
-
second-filing-notification-of-a-person-with-significant-control (2022-11-22) - RP04PSC02
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-11-25) - PSC05
-
second-filing-cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-12-09) - RP04PSC07
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-12-19) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-12-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-03-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-08-09) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-10-02) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-04) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-03-04) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-18) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-10-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-06) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-09-26) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-03) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-04) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-11-03) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-09-11) - SH01
-
resolution (2015-09-11) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-25) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-04-09) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-04) - NEWINC