-
AROMANTIC LIMITED - 39 South Street, Elgin, IV30 1JZ, United Kingdom, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC299277
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 39 South Street
- Elgin
- IV30 1JZ
- United Kingdom 39 South Street, Elgin, IV30 1JZ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BORSETH, Jon Benjamin
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.03.2006
- Alter der Firma 2006-03-21 18 Jahre
- SIC/NACE
- 47750
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Jon Benjamin Borseth
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2012-03-21
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-04-04
- Letzte Einreichung: 2023-03-21
-
AROMANTIC LIMITED Firmenbeschreibung
- AROMANTIC LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC299277. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 21.03.2006 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47750" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31/03/2011 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 21.03.2012.Die Firma kann schriftlich über 39 South Street erreicht werden.
Jetzt sichern AROMANTIC LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Aromantic Limited - 39 South Street, Elgin, IV30 1JZ, United Kingdom, Grossbritannien
- 2006-03-21
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu AROMANTIC LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-21) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2021-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-01-02) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-01-19) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-19) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-03) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-03) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-03) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-23) - CS01
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-06-08) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-10-06) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-31) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-16) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-07) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-12-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-04-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-17) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2013-10-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2012-12-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2012-03-29) - AR01
keyboard_arrow_right 2011
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2011-03-30) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-01-05) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2011-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2010
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2010-04-20) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2010-04-20) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2010-04-20) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2010-02-01) - AA
keyboard_arrow_right 2009
-
legacy (2009-04-14) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2009-02-02) - AA
keyboard_arrow_right 2008
-
legacy (2008-04-15) - 288c
-
legacy (2008-04-15) - 363a
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2008-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2007
-
legacy (2007-04-18) - 363a
keyboard_arrow_right 2006
-
incorporation-company (2006-03-21) - NEWINC