-
KRISTIN LINKLATER VOICE CENTRE LIMITED - Upper Housegarth, Quoyloo, Stromness, KW16 3LY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC421964
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Upper Housegarth
- Quoyloo
- Stromness
- KW16 3LY
- Scotland Upper Housegarth, Quoyloo, Stromness, KW16 3LY, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- LINKLATER, Magnus Duncan
- LINKLATER, Hamish Erik
- MANSON, Kenneth Hugh
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.04.2012
- Alter der Firma 2012-04-16 12 Jahre
- SIC/NACE
- 85520
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Kristin Linklater
- -
- Executors Of Ms Kristin Linklater
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2013-04-16
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-04-30
- Letzte Einreichung: 2022-04-16
-
KRISTIN LINKLATER VOICE CENTRE LIMITED Firmenbeschreibung
- KRISTIN LINKLATER VOICE CENTRE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC421964. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.04.2012 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85520" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 16.04.2013.Die Firma kann schriftlich über Upper Housegarth erreicht werden.
Jetzt sichern KRISTIN LINKLATER VOICE CENTRE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Kristin Linklater Voice Centre Limited - Upper Housegarth, Quoyloo, Stromness, KW16 3LY, Grossbritannien
- 2012-04-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu KRISTIN LINKLATER VOICE CENTRE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-19) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-07-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-10-27) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-10-27) - TM02
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-02-12) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-02-16) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-04-19) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-04-19) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-20) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-10) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-14) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-14) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-09-17) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-25) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-24) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-06-13) - AP03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-07) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-06-13) - TM02
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-21) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-29) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-30) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-07) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-12-03) - AA
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2015-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-20) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-20) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-05-05) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-01-15) - AA
keyboard_arrow_right 2013
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2013-04-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2012
-
capital-allotment-shares (2012-07-30) - SH01
-
incorporation-company (2012-04-16) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2012-12-11) - SH01