-
ECOSSE SUBSEA LIMITED - Building 3, Levels 2 And 3 Aberdeen International Business Park, Dyce Drive, Dyce, Aberdeen, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC496834
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Building 3, Levels 2 And 3 Aberdeen International Business Park
- Dyce Drive
- Dyce
- Aberdeen
- AB21 0BR
- Scotland Building 3, Levels 2 And 3 Aberdeen International Business Park, Dyce Drive, Dyce, Aberdeen, AB21 0BR, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- MCDONALD, Martin James
- SMITHWHITE, Desmond
- Prokuristen
- FRISBIE, Hilary
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.02.2015
- Gelöscht am:
- 2021-11-09
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Oceaneering International Services Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-03-05
- Letzte Einreichung: 2021-02-19
-
ECOSSE SUBSEA LIMITED Firmenbeschreibung
- ECOSSE SUBSEA LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC496834. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.02.2015 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Building 3, Levels 2 And 3 Aberdeen International Business Park erreicht werden.
Jetzt sichern ECOSSE SUBSEA LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ecosse Subsea Limited - Building 3, Levels 2 And 3 Aberdeen International Business Park, Dyce Drive, Dyce, Aberdeen, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ECOSSE SUBSEA LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
dissolution-voluntary-strike-off-suspended (2021-06-30) - SOAS(A)
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-26) - AA
-
dissolution-application-strike-off-company (2021-04-28) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2021-05-04) - GAZ1(A)
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-07-02) - TM01
-
gazette-dissolved-voluntary (2021-11-09) - GAZ2(A)
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-05-06) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-05-06) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-16) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-03-16) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-03-16) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-19) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-22) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-07-26) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-09-04) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-30) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-08) - AP01
-
resolution (2018-03-22) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-07) - TM01
-
resolution (2018-10-18) - RESOLUTIONS
-
legacy (2018-10-18) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2018-10-18) - SH19
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-28) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-03-07) - TM02
-
legacy (2018-10-18) - CAP-SS
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-07) - PSC07
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2018-03-07) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-07) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-03-07) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-02-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-01-04) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-25) - AP01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-07-13) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-07-19) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-17) - CS01
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-09-21) - SH08
-
resolution (2017-09-21) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-09) - AR01
-
resolution (2016-03-23) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-05-05) - RESOLUTIONS
-
resolution (2016-05-13) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-05-13) - SH08
-
capital-allotment-shares (2016-05-05) - SH01
-
resolution (2016-09-01) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-12-13) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-09-01) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-05-07) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2015-02-04) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-06-29) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-05-19) - AA01
-
capital-allotment-shares (2015-05-07) - SH01