-
YOUNG & PARTNERS BUSINESS LAWYERS LIMITED - 1 George Square, Castle Brae, Dunfermline, Fife, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- SC528615
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1 George Square
- Castle Brae
- Dunfermline
- Fife
- KY11 8QF
- Scotland 1 George Square, Castle Brae, Dunfermline, Fife, KY11 8QF, Scotland UK
Management
- Geschäftsführung
- CASSELLS, John Graham
- LOCHRIE, Stephen Richard
- STALKER, Alan Douglas
- WATERS, Ruth
- SMITH, Craig Joseph
- SULLIVAN, Julie Kathryn
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2016
- Alter der Firma 2016-03-03 8 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Young & Partners Business Lawyers (Corporate Services) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-16
- Letzte Einreichung: 2023-03-02
-
YOUNG & PARTNERS BUSINESS LAWYERS LIMITED Firmenbeschreibung
- YOUNG & PARTNERS BUSINESS LAWYERS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. SC528615. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.03.2016 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 6 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2023 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 1 George Square erreicht werden.
Jetzt sichern YOUNG & PARTNERS BUSINESS LAWYERS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Young & Partners Business Lawyers Limited - 1 George Square, Castle Brae, Dunfermline, Fife, Grossbritannien
- 2016-03-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu YOUNG & PARTNERS BUSINESS LAWYERS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-16) - CS01
-
capital-alter-shares-subdivision (2023-12-27) - SH02
-
memorandum-articles (2023-12-19) - MA
-
resolution (2023-12-19) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-11-14) - AA
-
capital-allotment-shares (2022-04-29) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-04-04) - CH01
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-01-07) - SH03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2022-04-04) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2022-03-15) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-02-28) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-02-28) - PSC07
-
capital-cancellation-shares (2022-01-07) - SH06
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-14) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-20) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-04-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-03-23) - CH01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-11-02) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-11-02) - PSC04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-03-13) - CS01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-02-19) - SH19
-
legacy (2020-02-19) - SH20
-
legacy (2020-02-19) - CAP-SS
-
resolution (2020-02-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-03-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-09) - TM01
-
resolution (2019-03-14) - RESOLUTIONS
-
legacy (2019-03-14) - CAP-SS
-
legacy (2019-03-14) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-03-14) - SH19
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-11-08) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-11-30) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-11-07) - SH01
-
resolution (2017-11-03) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-03-23) - SH08
-
resolution (2016-03-23) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-23) - AP01
-
incorporation-company (2016-03-03) - NEWINC
-
capital-allotment-shares (2016-03-23) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-27) - MR01